Pitard.net - Buffalo Family

New York State



 


Country : Latitude: 42.616645309, Longitude: -75.785757956


Birth

Matches 1 to 193 of 193

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Elizabeth  Abt 1906New York State I284
2 Elizabeth  Abt 1909New York State I1222
3 Mary  Aug 1863New York State I1092
4 Barry, Theresa C.  Abt 1855New York State I503
5 Battista, Ellen  Abt 1903New York State I244
6 Battista, Luigi "Louis"  17 Sep 1897New York State I246
7 Battista, Margaret "Maggie"  3 Dec 1899New York State I248
8 Battista, Mildred "Millie"  Abt 1915New York State I254
9 Battista, Nancy  29 Apr 1902New York State I245
10 Battista, Rosina "Rose"  23 Mar 1892New York State I255
11 Battista, Thomas "Honey"  18 Feb 1906New York State I252
12 Berst, Edward  Jul 1885New York State I1198
13 Berst, Gertrude  Jul 1891New York State I1196
14 Berst, Lillian  Apr 1882New York State I1199
15 Berst, Mary  Mar 1858New York State I1194
16 Berst, Mary  Jan 1890New York State I1197
17 Berst, Peter  Oct 1855New York State I1195
18 Biesanz, Michael  Abt 1854New York State I883
19 Bisantz, Augusta  Abt 1847New York State I771
20 Bisantz, Catherine M.  Mar 1840New York State I767
21 Bisantz, Charles  Abt 1845New York State I884
22 Bisantz, Dominic "Daniel"  Abt 1849New York State I765
23 Bisantz, Frank J.  Abt 1849New York State I882
24 Bisantz, John  Abt 1839New York State I879
25 Bisantz, Mary  Abt 1841New York State I880
26 Bisantz, Mary Elizabeth  6 Dec 1842New York State I768
27 Bisantz, Mary Magdalena  3 Feb 1838New York State I772
28 Bisky, Marcella Patricia  Abt 1902New York State I1086
29 Bouquard, Andrea  Dec 1885New York State I1018
30 Bouquard, Frank  Jan 1881New York State I1020
31 Bouquard, Harry  Apr 1890New York State I1016
32 Bouquard, Joseph  Abt 1854New York State I1013
33 Bouquard, Josephine  Jun 1896New York State I1014
34 Bouquard, Kate  Dec 1888New York State I1015
35 Bouquard, Peter  Sep 1882New York State I1019
36 Buckley, Adeline  Abt 1878New York State I1079
37 Caldiero, Mary  Abt 1913New York State I232
38 Clare, Mary Sophia  1860New York State I1043
39 Clark, Anna  Mar 1867New York State I983
40 Clark, Bridget  Abt 1858New York State I981
41 Clark, Elizabeth "Libbie"  Abt 1868New York State I985
42 Clark, Fannie  Abt 1858New York State I976
43 Clark, James  Aug 1862New York State I978
44 Clark, Maria  Abt 1860New York State I980
45 Clark, Martha  Abt 1861New York State I986
46 Clark, Michael  Abt 1873New York State I984
47 Clark, Peter  Abt 1864New York State I979
48 Clark, Thomas  Abt 1856New York State I3
49 Clark, William J. "Bill"  Abt 1902New York State I1080
50 Collins, Anthony  May 1872New York State I545
51 Collins, Henry  Jul 1868New York State I544
52 Colpoys, Agnes F.  14 Jun 1907New York State I1211
53 Colpoys, Arthur M.  13 Jan 1902New York State I1213
54 Colpoys, Cecelia M.  Abt 1909New York State I1217
55 Colpoys, Edward "Eddie" J.  22 Jul 1912New York State I784
56 Colpoys, Francis T.  Abt 1910New York State I1210
57 Colpoys, Henry F.  26 Sep 1905New York State I1212
58 Colpoys, Lillian  19 Nov 1903New York State I1215
59 Colpoys, Mae  21 Feb 1900New York State I1214
60 Colpoys, Matthew  25 Sep 1936New York State I785
61 Corigliano, Angeline  Abt 1912New York State I344
62 Corigliano, Grace  Abt 1920New York State I358
63 Corigliano, Lucy  Abt 1915New York State I359
64 Corigliano, Philip  Abt 1914New York State I360
65 Corigliano, Rose  Abt 1895New York State I347
66 Corigliano, Samuel  Abt 1923New York State I357
67 Cuoco, Albert  28 Oct 1921New York State I278
68 Cuoco, Angelo  6 Dec 1932New York State I280
69 Cuoco, Concetta  Abt 1926New York State I277
70 Cuoco, Theresa "Cookie"  Abt 1919New York State I279
71 Darsheimer, Ethel  Abt 1894New York State I907
72 Denzinger, Charles  Abt 1866New York State I833
73 Denzinger, Julius  Abt 1870New York State I831
74 Denzinger, Olivia  Abt 1868New York State I832
75 Farnes, Anthony  Abt 1850New York State I1054
76 Farnes, Clara  Jul 1873New York State I365
77 Flanigan, Charlotte  Oct 1857New York State I1226
78 Flanigan, Charlotte  Dec 1892New York State I1233
79 Flanigan, Helen  Apr 1894New York State I1232
80 Flanigan, James T.  Mar 1890New York State I1234
81 Forster, Lucille Catherine  15 Apr 1921New York State I1230
82 Fries, Blanche  Feb 1892New York State I996
83 Fries, Charles  Abt 1853New York State I859
84 Fries, Charles  Abt 1877New York State I998
85 Fries, Joseph  Apr 1887New York State I997
86 Fries, Louis  May 1885New York State I860
87 Fries, Walter  Aug 1881New York State I999
88 Gallagher, Irene M  Abt 1892New York State I973
89 Jordan, Anna  May 1883New York State I945
90 Jordan, Henry  Sep 1882New York State I949
91 Jordan, John  Abt 1849New York State I936
92 Jordan, Joseph E  Abt 1914New York State I972
93 Jordan, Joseph S.  Jul 1892New York State I948
94 Jordan, M. Katherine  1907New York State I724
95 Jordan, Mary  Aug 1890New York State I946
96 Jordan, Mary  Abt 1924New York State I728
97 Jordan, Matthew W.  9 Aug 1882New York State I714
98 Jordan, Rita  Abt 1915New York State I723
99 Jordan, William  Jan 1887New York State I947
100 Jordan, William Lee  Abt 1915New York State I971
101 Kingsland, Gordon  9 Nov 1915New York State I350
102 Kingsland, Walter  Abt 1902New York State I388
103 Licino, Felicia “Chicky”  13 Mar 1913New York State I261
104 Logalbo, Antonina "Nina"  Abt 1915New York State I324
105 Logalbo, Joseph  Abt 1912New York State I325
106 Logalbo, Vincent C. "Jimmy"  30 Sep 1912New York State I215
107 Martin, Carl  Abt 1905New York State I1228
108 McCormick, Mary  Abt 1858New York State I741
109 McMullen, Anne Marie  Nov 1894New York State I1071
110 McMullen, Clark Augustine  20 Jan 1890New York State I1069
111 McMullen, Frances "Fannie"  Nov 1886New York State I1073
112 McMullen, Frederic J. “Fred”  Jul 1888New York State I1070
113 McMullen, James "Jim" W.  Apr 1860New York State I1068
114 McMullen, Matilda "Tillie"  Jun 1885New York State I1072
115 Moser, Anna E.  Oct 1855New York State I721
116 Moser, Frederick  Abt 1855New York State I959
117 Moser, Fredericka  Abt 1858New York State I958
118 Nicholas, Elizabeth  Abt 1859New York State I1240
119 Nichols, Catherine  Abt 1863New York State I1239
120 Nichols, Charles  Abt 1861New York State I1241
121 Nichols, Eva  Abt 1876New York State I1244
122 Nichols, Lottie  Abt 1878New York State I1243
123 Nichols, Mary Bell  Abt 1872New York State I1238
124 Nichols, Nellie  Abt 1875New York State I1237
125 Nichols, Robert  Abt Mar 1880New York State I1242
126 Okoski, Ida  Abt 1873New York State I1035
127 Palermo, Carmine "Charlie"  22 Aug 1913New York State I218
128 Palermo, Fannie  Abt Dec 1909New York State I262
129 Palermo, Felicia A. "Fanny"  Jan 1912New York State I214
130 Palermo, Theresa  Abt 1914New York State I264
131 Palermo, Thomas  Abt 1915New York State I263
132 Paolucci, Angeline Frances  Abt 1919New York State I361
133 Paolucci, Clara  21 Jan 1923New York State I364
134 Paolucci, Dominick  Abt 1927New York State I363
135 Paolucci, Guido  Abt 1921New York State I362
136 Paolucci, Serafino  17 Feb 1915New York State I369
137 Paul, Anthony M.  Abt 1879New York State I1038
138 Paul, Florence M.  Abt 1908New York State I1039
139 Paul, Loretta A.  Abt 1909New York State I1040
140 Ramé, Anthony  Abt 1847New York State I857
141 Ramé, Lewis  Abt 1837New York State I854
142 Ramé, Margaret Victoria  Jun 1848New York State I852
143 Ramé, Marian  Mar 1847New York State I853
144 Ramé, Valentine  Abt 1841New York State I855
145 Reinhardt, Dominia  Abt 1858New York State I1193
146 Reinhardt, Emma  Apr 1878New York State I1060
147 Reinhardt, Frank  Abt 1860New York State I1192
148 Reinhardt, Joseph  Dec 1851New York State I1055
149 Reinhardt, Magdalene  Abt 1854New York State I1191
150 Reinhardt, Philipine  Abt 1856New York State I1190
151 Reinhart, James  May 1884New York State I1063
152 Reinhart, Jennie  Jan 1881New York State I1059
153 Reinhart, John P  Nov 1889New York State I1061
154 Reinhart, Martha A  May 1884New York State I1064
155 Reinhart, Phillipana  May 1882New York State I1065
156 Reinhart, William  Aug 1885New York State I1062
157 Salos, Elizabeth  Abt 1918New York State I323
158 Schwenk, Christian Burton  14 May 1951New York State I754
159 Sigeti, Anna V  Abt 1913New York State I339
160 Sigeti, Anthony J  25 Jun 1921New York State I326
161 Sigeti, Bertha F  Abt 1922New York State I328
162 Sigeti, Frank W  Abt 1927New York State I330
163 Sigeti, Helen E  Abt 1917New York State I333
164 Sigeti, Julia C  Abt 1914New York State I334
165 Sigeti, Marie I.  29 Nov 1911New York State I294
166 Sigeti, Steve  Abt 1919New York State I332
167 Smith, John J.  Oct 1852New York State I475
168 Stephan, Amalia  Abt 1862New York State I991
169 Stephan, Levina  Abt 1869New York State I989
170 Stephan, Rosa  Abt 1864New York State I990
171 Strohe, Florence  11 Dec 1889New York State I918
172 Tobin, Charles  Abt 1878New York State I899
173 Tobin, Joseph  14 Sep 1890New York State I894
174 Tobin, Mary  Abt 1876New York State I900
175 Tobin, Thomas Albert  15 Nov 1893New York State I893
176 Valiquette, Amelia  Abt 1852New York State I1010
177 Valiquette, George C.  Abt 1864New York State I1034
178 Valiquette, John  Abt 1862New York State I1037
179 Valiquette, Peter  Feb 1855New York State I738
180 Ververs, Mary V  Abt 1903New York State I1128
181 Voght, Louis  Abt 1874New York State I820
182 Vogt, Arthur W.  Abt 1886New York State I813
183 Vogt, Cary  Abt 1872New York State I818
184 Vogt, Cora  Abt 1884New York State I816
185 Vogt, Eugene  Abt 1866New York State I821
186 Vogt, Laura  Abt Feb 1870New York State I814
187 Vogt, Leon  Abt 1874New York State I817
188 Willman, Clara  Abt 1874New York State I823
189 Willman, Ida  Abt 1878New York State I824
190 Willman, Joseph  Abt 1869New York State I829
191 Willman, Julie  Abt Apr 1870New York State I827
192 Willman, Leo  Abt 1876New York State I828
193 Willman, Mary Eleanor  Abt 1867New York State I826

Death

Matches 1 to 8 of 8

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID 
1 Catharine  Bef 1900New York State I777
2 Bisantz, Anthony Edward Jr.  16 Apr 1875New York State I739
3 Flanigan, John  8 Nov 1963New York State I327
4 Flanigan, William J.  28 Jun 1961New York State I911
5 Kingsland, Gordon  Abt Jul 1979New York State I350
6 Licino, Felicia “Chicky”  20 Dec 1999New York State I261
7 McNamara, Delia  11 Dec 1964New York State I788
8 Santercole, Louis V.  27 Jan 2015New York State I1231

Arrival

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Arrival    Person ID 
1 Licino, Michael "Mike"  7 Mar 1919New York State I260

Birth

Matches 1 to 9 of 9

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Berst, Dorothy  Abt 1923New York State I962
2 Bisantz, Dominic "Daniel"  12 May 1849New York State I765
3 Bisantz, Mary  Abt 1846New York State I880
4 Caldiero, Carmine  Abt 1916New York State I343
5 Clare, Julia  Abt 1867New York State I1047
6 Clare, Mary Ann  4 Aug 1872New York State I1045
7 Clark, Michael John  Abt 1906New York State I1078
8 Flanigan, Helen Louse  Abt 1926New York State I909
9 Okoski, Ida  Mar 1873New York State I1035

Death

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID 
1 Kingsland, Gordon  17 Jul 1979New York State I350

Military Service Record

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Military Service Record    Person ID 
1 McCormick, Philip  10 Oct 1864New York State I794

Residence

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID 
1 Sigeti, Anthony J  New York State I326