Pitard.net - Buffalo Family

New York State



 


Country : Latitude: 42.616645309, Longitude: -75.785757956


Birth

Matches 1 to 193 of 193

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Ramé, Lewis  Abt 1837New York State I854
2 Bisantz, Mary Magdalena  3 Feb 1838New York State I772
3 Bisantz, John  Abt 1839New York State I879
4 Bisantz, Catherine M.  Mar 1840New York State I767
5 Bisantz, Mary  Abt 1841New York State I880
6 Ramé, Valentine  Abt 1841New York State I855
7 Bisantz, Mary Elizabeth  6 Dec 1842New York State I768
8 Bisantz, Charles  Abt 1845New York State I884
9 Bisantz, Augusta  Abt 1847New York State I771
10 Ramé, Anthony  Abt 1847New York State I857
11 Ramé, Marian  Mar 1847New York State I853
12 Ramé, Margaret Victoria  Jun 1848New York State I852
13 Bisantz, Dominic "Daniel"  Abt 1849New York State I765
14 Bisantz, Frank J.  Abt 1849New York State I882
15 Jordan, John  Abt 1849New York State I936
16 Farnes, Anthony  Abt 1850New York State I1054
17 Reinhardt, Joseph  Dec 1851New York State I1055
18 Valiquette, Amelia  Abt 1852New York State I1010
19 Smith, John J.  Oct 1852New York State I475
20 Fries, Charles  Abt 1853New York State I859
21 Biesanz, Michael  Abt 1854New York State I883
22 Bouquard, Joseph  Abt 1854New York State I1013
23 Reinhardt, Magdalene  Abt 1854New York State I1191
24 Barry, Theresa C.  Abt 1855New York State I503
25 Moser, Frederick  Abt 1855New York State I959
26 Valiquette, Peter  Feb 1855New York State I738
27 Berst, Peter  Oct 1855New York State I1195
28 Moser, Anna E.  Oct 1855New York State I721
29 Clark, Thomas  Abt 1856New York State I3
30 Reinhardt, Philipine  Abt 1856New York State I1190
31 Flanigan, Charlotte  Oct 1857New York State I1226
32 Clark, Bridget  Abt 1858New York State I981
33 Clark, Fannie  Abt 1858New York State I976
34 McCormick, Mary  Abt 1858New York State I741
35 Moser, Fredericka  Abt 1858New York State I958
36 Reinhardt, Dominia  Abt 1858New York State I1193
37 Berst, Mary  Mar 1858New York State I1194
38 Nicholas, Elizabeth  Abt 1859New York State I1240
39 Clare, Mary Sophia  1860New York State I1043
40 Clark, Maria  Abt 1860New York State I980
41 Reinhardt, Frank  Abt 1860New York State I1192
42 McMullen, James "Jim" W.  Apr 1860New York State I1068
43 Clark, Martha  Abt 1861New York State I986
44 Nichols, Charles  Abt 1861New York State I1241
45 Stephan, Amalia  Abt 1862New York State I991
46 Valiquette, John  Abt 1862New York State I1037
47 Clark, James  Aug 1862New York State I978
48 Nichols, Catherine  Abt 1863New York State I1239
49 Mary  Aug 1863New York State I1092
50 Clark, Peter  Abt 1864New York State I979
51 Stephan, Rosa  Abt 1864New York State I990
52 Valiquette, George C.  Abt 1864New York State I1034
53 Denzinger, Charles  Abt 1866New York State I833
54 Vogt, Eugene  Abt 1866New York State I821
55 Willman, Mary Eleanor  Abt 1867New York State I826
56 Clark, Anna  Mar 1867New York State I983
57 Clark, Elizabeth "Libbie"  Abt 1868New York State I985
58 Denzinger, Olivia  Abt 1868New York State I832
59 Collins, Henry  Jul 1868New York State I544
60 Stephan, Levina  Abt 1869New York State I989
61 Willman, Joseph  Abt 1869New York State I829
62 Denzinger, Julius  Abt 1870New York State I831
63 Vogt, Laura  Abt Feb 1870New York State I814
64 Willman, Julie  Abt Apr 1870New York State I827
65 Nichols, Mary Bell  Abt 1872New York State I1238
66 Vogt, Cary  Abt 1872New York State I818
67 Collins, Anthony  May 1872New York State I545
68 Clark, Michael  Abt 1873New York State I984
69 Okoski, Ida  Abt 1873New York State I1035
70 Farnes, Clara  Jul 1873New York State I365
71 Voght, Louis  Abt 1874New York State I820
72 Vogt, Leon  Abt 1874New York State I817
73 Willman, Clara  Abt 1874New York State I823
74 Nichols, Nellie  Abt 1875New York State I1237
75 Nichols, Eva  Abt 1876New York State I1244
76 Tobin, Mary  Abt 1876New York State I900
77 Willman, Leo  Abt 1876New York State I828
78 Fries, Charles  Abt 1877New York State I998
79 Buckley, Adeline  Abt 1878New York State I1079
80 Nichols, Lottie  Abt 1878New York State I1243
81 Tobin, Charles  Abt 1878New York State I899
82 Willman, Ida  Abt 1878New York State I824
83 Reinhardt, Emma  Apr 1878New York State I1060
84 Paul, Anthony M.  Abt 1879New York State I1038
85 Nichols, Robert  Abt Mar 1880New York State I1242
86 Bouquard, Frank  Jan 1881New York State I1020
87 Reinhart, Jennie  Jan 1881New York State I1059
88 Fries, Walter  Aug 1881New York State I999
89 Berst, Lillian  Apr 1882New York State I1199
90 Reinhart, Phillipana  May 1882New York State I1065
91 Jordan, Matthew W.  9 Aug 1882New York State I714
92 Bouquard, Peter  Sep 1882New York State I1019
93 Jordan, Henry  Sep 1882New York State I949
94 Jordan, Anna  May 1883New York State I945
95 Vogt, Cora  Abt 1884New York State I816
96 Reinhart, James  May 1884New York State I1063
97 Reinhart, Martha A  May 1884New York State I1064
98 Fries, Louis  May 1885New York State I860
99 McMullen, Matilda "Tillie"  Jun 1885New York State I1072
100 Berst, Edward  Jul 1885New York State I1198
101 Reinhart, William  Aug 1885New York State I1062
102 Bouquard, Andrea  Dec 1885New York State I1018
103 Vogt, Arthur W.  Abt 1886New York State I813
104 McMullen, Frances "Fannie"  Nov 1886New York State I1073
105 Jordan, William  Jan 1887New York State I947
106 Fries, Joseph  Apr 1887New York State I997
107 McMullen, Frederic J. “Fred”  Jul 1888New York State I1070
108 Bouquard, Kate  Dec 1888New York State I1015
109 Reinhart, John P  Nov 1889New York State I1061
110 Strohe, Florence  11 Dec 1889New York State I918
111 Berst, Mary  Jan 1890New York State I1197
112 McMullen, Clark Augustine  20 Jan 1890New York State I1069
113 Flanigan, James T.  Mar 1890New York State I1234
114 Bouquard, Harry  Apr 1890New York State I1016
115 Jordan, Mary  Aug 1890New York State I946
116 Tobin, Joseph  14 Sep 1890New York State I894
117 Berst, Gertrude  Jul 1891New York State I1196
118 Gallagher, Irene M  Abt 1892New York State I973
119 Fries, Blanche  Feb 1892New York State I996
120 Battista, Rosina "Rose"  23 Mar 1892New York State I255
121 Jordan, Joseph S.  Jul 1892New York State I948
122 Flanigan, Charlotte  Dec 1892New York State I1233
123 Tobin, Thomas Albert  15 Nov 1893New York State I893
124 Darsheimer, Ethel  Abt 1894New York State I907
125 Flanigan, Helen  Apr 1894New York State I1232
126 McMullen, Anne Marie  Nov 1894New York State I1071
127 Corigliano, Rose  Abt 1895New York State I347
128 Bouquard, Josephine  Jun 1896New York State I1014
129 Battista, Luigi "Louis"  17 Sep 1897New York State I246
130 Battista, Margaret "Maggie"  3 Dec 1899New York State I248
131 Colpoys, Mae  21 Feb 1900New York State I1214
132 Bisky, Marcella Patricia  Abt 1902New York State I1086
133 Clark, William J. "Bill"  Abt 1902New York State I1080
134 Kingsland, Walter  Abt 1902New York State I388
135 Colpoys, Arthur M.  13 Jan 1902New York State I1213
136 Battista, Nancy  29 Apr 1902New York State I245
137 Battista, Ellen  Abt 1903New York State I244
138 Ververs, Mary V  Abt 1903New York State I1128
139 Colpoys, Lillian  19 Nov 1903New York State I1215
140 Martin, Carl  Abt 1905New York State I1228
141 Colpoys, Henry F.  26 Sep 1905New York State I1212
142 Elizabeth  Abt 1906New York State I284
143 Battista, Thomas "Honey"  18 Feb 1906New York State I252
144 Jordan, M. Katherine  1907New York State I724
145 Colpoys, Agnes F.  14 Jun 1907New York State I1211
146 Paul, Florence M.  Abt 1908New York State I1039
147 Elizabeth  Abt 1909New York State I1222
148 Colpoys, Cecelia M.  Abt 1909New York State I1217
149 Paul, Loretta A.  Abt 1909New York State I1040
150 Palermo, Fannie  Abt Dec 1909New York State I262
151 Colpoys, Francis T.  Abt 1910New York State I1210
152 Sigeti, Marie I.  29 Nov 1911New York State I294
153 Corigliano, Angeline  Abt 1912New York State I344
154 Logalbo, Joseph  Abt 1912New York State I325
155 Palermo, Felicia A. "Fanny"  Jan 1912New York State I214
156 Colpoys, Edward "Eddie" J.  22 Jul 1912New York State I784
157 Logalbo, Vincent C. "Jimmy"  30 Sep 1912New York State I215
158 Caldiero, Mary  Abt 1913New York State I232
159 Sigeti, Anna V  Abt 1913New York State I339
160 Licino, Felicia “Chicky”  13 Mar 1913New York State I261
161 Palermo, Carmine "Charlie"  22 Aug 1913New York State I218
162 Corigliano, Philip  Abt 1914New York State I360
163 Jordan, Joseph E  Abt 1914New York State I972
164 Palermo, Theresa  Abt 1914New York State I264
165 Sigeti, Julia C  Abt 1914New York State I334
166 Battista, Mildred "Millie"  Abt 1915New York State I254
167 Corigliano, Lucy  Abt 1915New York State I359
168 Jordan, Rita  Abt 1915New York State I723
169 Jordan, William Lee  Abt 1915New York State I971
170 Logalbo, Antonina "Nina"  Abt 1915New York State I324
171 Palermo, Thomas  Abt 1915New York State I263
172 Paolucci, Serafino  17 Feb 1915New York State I369
173 Kingsland, Gordon  9 Nov 1915New York State I350
174 Sigeti, Helen E  Abt 1917New York State I333
175 Salos, Elizabeth  Abt 1918New York State I323
176 Cuoco, Theresa "Cookie"  Abt 1919New York State I279
177 Paolucci, Angeline Frances  Abt 1919New York State I361
178 Sigeti, Steve  Abt 1919New York State I332
179 Corigliano, Grace  Abt 1920New York State I358
180 Paolucci, Guido  Abt 1921New York State I362
181 Forster, Lucille Catherine  15 Apr 1921New York State I1230
182 Sigeti, Anthony J  25 Jun 1921New York State I326
183 Cuoco, Albert  28 Oct 1921New York State I278
184 Sigeti, Bertha F  Abt 1922New York State I328
185 Corigliano, Samuel  Abt 1923New York State I357
186 Paolucci, Clara  21 Jan 1923New York State I364
187 Jordan, Mary  Abt 1924New York State I728
188 Cuoco, Concetta  Abt 1926New York State I277
189 Paolucci, Dominick  Abt 1927New York State I363
190 Sigeti, Frank W  Abt 1927New York State I330
191 Cuoco, Angelo  6 Dec 1932New York State I280
192 Colpoys, Matthew  25 Sep 1936New York State I785
193 Schwenk, Christian Burton  14 May 1951New York State I754

Death

Matches 1 to 8 of 8

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID 
1 Bisantz, Anthony Edward Jr.  16 Apr 1875New York State I739
2 Catharine  Bef 1900New York State I777
3 Flanigan, William J.  28 Jun 1961New York State I911
4 Flanigan, John  8 Nov 1963New York State I327
5 McNamara, Delia  11 Dec 1964New York State I788
6 Kingsland, Gordon  Abt Jul 1979New York State I350
7 Licino, Felicia “Chicky”  20 Dec 1999New York State I261
8 Santercole, Louis V.  27 Jan 2015New York State I1231

Arrival

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Arrival    Person ID 
1 Licino, Michael "Mike"  7 Mar 1919New York State I260

Birth

Matches 1 to 9 of 9

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Bisantz, Mary  Abt 1846New York State I880
2 Bisantz, Dominic "Daniel"  12 May 1849New York State I765
3 Clare, Julia  Abt 1867New York State I1047
4 Clare, Mary Ann  4 Aug 1872New York State I1045
5 Okoski, Ida  Mar 1873New York State I1035
6 Clark, Michael John  Abt 1906New York State I1078
7 Caldiero, Carmine  Abt 1916New York State I343
8 Berst, Dorothy  Abt 1923New York State I962
9 Flanigan, Helen Louse  Abt 1926New York State I909

Death

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID 
1 Kingsland, Gordon  17 Jul 1979New York State I350

Military Service Record

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Military Service Record    Person ID 
1 McCormick, Philip  10 Oct 1864New York State I794

Residence

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID 
1 Sigeti, Anthony J  New York State I326