Pitard.net - Buffalo Family

New York State



 


Country : Latitude: 42.616645309, Longitude: -75.785757956


Birth

Matches 1 to 190 of 190

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Elizabeth  Abt 1906New York State I284
2 Elizabeth  Abt 1909New York State I1222
3 Mary  Aug 1863New York State I1092
4 Battista, Ellen  Abt 1903New York State I244
5 Battista, Luigi "Louis"  17 Sep 1897New York State I246
6 Battista, Margaret "Maggie"  3 Dec 1899New York State I248
7 Battista, Mildred "Millie"  Abt 1915New York State I254
8 Battista, Nancy  29 Apr 1902New York State I245
9 Battista, Rosina "Rose"  23 Mar 1892New York State I255
10 Battista, Thomas  18 Feb 1906New York State I252
11 Berst, Edward  Jul 1885New York State I1198
12 Berst, Gertrude  Jul 1891New York State I1196
13 Berst, Lillian  Apr 1882New York State I1199
14 Berst, Mary  Mar 1858New York State I1194
15 Berst, Mary  Jan 1890New York State I1197
16 Berst, Peter  Oct 1855New York State I1195
17 Biesanz, Michael  Abt 1854New York State I883
18 Bisantz, Augusta  Abt 1847New York State I771
19 Bisantz, Catherine M.  Mar 1840New York State I767
20 Bisantz, Charles  Abt 1845New York State I884
21 Bisantz, Dominic "Daniel"  Abt 1849New York State I765
22 Bisantz, Frank J.  Abt 1849New York State I882
23 Bisantz, John  Abt 1839New York State I879
24 Bisantz, Mary  Abt 1841New York State I880
25 Bisantz, Mary Elizabeth  6 Dec 1842New York State I768
26 Bisantz, Mary Magdalena  3 Feb 1838New York State I772
27 Bisky, Marcella Patricia  Abt 1902New York State I1086
28 Bouquard, Andrea  Dec 1885New York State I1018
29 Bouquard, Frank  Jan 1881New York State I1020
30 Bouquard, Harry  Apr 1890New York State I1016
31 Bouquard, Joseph  Abt 1854New York State I1013
32 Bouquard, Josephine  Jun 1896New York State I1014
33 Bouquard, Kate  Dec 1888New York State I1015
34 Bouquard, Peter  Sep 1882New York State I1019
35 Buckley, Adeline  Abt 1878New York State I1079
36 Caldiero, Mary  Abt 1913New York State I232
37 Clare, Mary Sophia  1860New York State I1043
38 Clark, Anna  Mar 1867New York State I983
39 Clark, Bridget  Abt 1858New York State I981
40 Clark, Elizabeth "Libbie"  Abt 1868New York State I985
41 Clark, Fannie  Abt 1858New York State I976
42 Clark, James  Aug 1862New York State I978
43 Clark, Maria  Abt 1860New York State I980
44 Clark, Martha  Abt 1861New York State I986
45 Clark, Michael  Abt 1873New York State I984
46 Clark, Peter  Abt 1864New York State I979
47 Clark, Thomas  Abt 1856New York State I3
48 Clark, William J. "Bill"  Abt 1902New York State I1080
49 Collins, Anthony  May 1872New York State I545
50 Collins, Henry  Jul 1868New York State I544
51 Colpoys, Agnes F.  14 Jun 1907New York State I1211
52 Colpoys, Arthur M.  13 Jan 1902New York State I1213
53 Colpoys, Cecelia M.  Abt 1909New York State I1217
54 Colpoys, Edward "Eddie" J.  22 Jul 1912New York State I784
55 Colpoys, Francis T.  Abt 1910New York State I1210
56 Colpoys, Henry F.  26 Sep 1905New York State I1212
57 Colpoys, Lillian  19 Nov 1903New York State I1215
58 Colpoys, Mae  21 Feb 1900New York State I1214
59 Colpoys, Matthew  25 Sep 1936New York State I785
60 Corigliano, Angeline  Abt 1912New York State I344
61 Corigliano, Grace  Abt 1920New York State I358
62 Corigliano, Lucy  Abt 1915New York State I359
63 Corigliano, Philip  Abt 1914New York State I360
64 Corigliano, Rose  Abt 1895New York State I347
65 Cuoco, Albert  28 Oct 1921New York State I278
66 Cuoco, Angelo  6 Dec 1932New York State I280
67 Cuoco, Concetta  Abt 1926New York State I277
68 Cuoco, Theresa "Cookie"  Abt 1919New York State I279
69 Darsheimer, Ethel  Abt 1894New York State I907
70 Denzinger, Charles  Abt 1866New York State I833
71 Denzinger, Julius  Abt 1870New York State I831
72 Denzinger, Olivia  Abt 1868New York State I832
73 Farnes, Anthony  Abt 1850New York State I1054
74 Farnes, Clara  Jul 1873New York State I365
75 Flanigan, Charlotte  Oct 1857New York State I1226
76 Flanigan, Charlotte  Dec 1892New York State I1233
77 Flanigan, Helen  Apr 1894New York State I1232
78 Flanigan, James T.  Mar 1890New York State I1234
79 Forster, Lucille Catherine  15 Apr 1921New York State I1230
80 Fries, Blanche  Feb 1892New York State I996
81 Fries, Charles  Abt 1853New York State I859
82 Fries, Charles  Abt 1877New York State I998
83 Fries, Joseph  Apr 1887New York State I997
84 Fries, Louis  May 1885New York State I860
85 Fries, Walter  Aug 1881New York State I999
86 Gallagher, Irene M  Abt 1892New York State I973
87 Jordan, Anna  May 1883New York State I945
88 Jordan, Henry  Sep 1882New York State I949
89 Jordan, John  Abt 1849New York State I936
90 Jordan, Joseph E  Abt 1914New York State I972
91 Jordan, Joseph S.  Jul 1892New York State I948
92 Jordan, M. Katherine  1907New York State I724
93 Jordan, Mary  Aug 1890New York State I946
94 Jordan, Mary  Abt 1924New York State I728
95 Jordan, Matthew W.  9 Aug 1882New York State I714
96 Jordan, Rita  Abt 1915New York State I723
97 Jordan, William  Jan 1887New York State I947
98 Jordan, William Lee  Abt 1915New York State I971
99 Kingsland, Gordon  9 Nov 1915New York State I350
100 Kingsland, Walter  Abt 1902New York State I388
101 Licino, Felicia “Chicky”  13 Mar 1913New York State I261
102 Logalbo, Antonina "Nina"  Abt 1915New York State I324
103 Logalbo, Joseph  Abt 1912New York State I325
104 Logalbo, Vincent C. "Jimmy"  30 Sep 1912New York State I215
105 Martin, Carl  Abt 1905New York State I1228
106 McCormick, Mary  Abt 1858New York State I741
107 McMullen, Anne Marie  Nov 1894New York State I1071
108 McMullen, Clark Augustine  20 Jan 1890New York State I1069
109 McMullen, Frances "Fannie"  Nov 1886New York State I1073
110 McMullen, Frederic J. “Fred”  Jul 1888New York State I1070
111 McMullen, James "Jim" W.  Apr 1860New York State I1068
112 McMullen, Matilda "Tillie"  Jun 1885New York State I1072
113 Moser, Anna E.  Oct 1855New York State I721
114 Moser, Frederick  Abt 1855New York State I959
115 Moser, Fredericka  Abt 1858New York State I958
116 Nicholas, Elizabeth  Abt 1859New York State I1240
117 Nichols, Catherine  Abt 1863New York State I1239
118 Nichols, Charles  Abt 1861New York State I1241
119 Nichols, Eva  Abt 1876New York State I1244
120 Nichols, Lottie  Abt 1878New York State I1243
121 Nichols, Mary Bell  Abt 1872New York State I1238
122 Nichols, Nellie  Abt 1875New York State I1237
123 Nichols, Robert  Abt Mar 1880New York State I1242
124 Okoski, Ida  Abt 1873New York State I1035
125 Palermo, Carmine "Charlie"  22 Aug 1913New York State I218
126 Palermo, Fannie  Abt Dec 1909New York State I262
127 Palermo, Felicia A. "Fanny"  Abt 1912New York State I214
128 Palermo, Theresa  Abt 1914New York State I264
129 Palermo, Thomas  Abt 1915New York State I263
130 Paolucci, Angeline Frances  Abt 1919New York State I361
131 Paolucci, Clara  21 Jan 1923New York State I364
132 Paolucci, Dominick  Abt 1927New York State I363
133 Paolucci, Guido  Abt 1921New York State I362
134 Paolucci, Serafino  17 Feb 1915New York State I369
135 Paul, Anthony M.  Abt 1879New York State I1038
136 Paul, Florence M.  Abt 1908New York State I1039
137 Paul, Loretta A.  Abt 1909New York State I1040
138 Ramé, Anthony  Abt 1847New York State I857
139 Ramé, Lewis  Abt 1837New York State I854
140 Ramé, Margaret Victoria  Jun 1848New York State I852
141 Ramé, Marian  Mar 1847New York State I853
142 Ramé, Valentine  Abt 1841New York State I855
143 Reinhardt, Dominia  Abt 1858New York State I1193
144 Reinhardt, Emma  Apr 1878New York State I1060
145 Reinhardt, Frank  Abt 1860New York State I1192
146 Reinhardt, Joseph  Dec 1851New York State I1055
147 Reinhardt, Magdalene  Abt 1854New York State I1191
148 Reinhardt, Philipine  Abt 1856New York State I1190
149 Reinhart, James  May 1884New York State I1063
150 Reinhart, Jennie  Jan 1881New York State I1059
151 Reinhart, John P  Nov 1889New York State I1061
152 Reinhart, Martha A  May 1884New York State I1064
153 Reinhart, Phillipana  May 1882New York State I1065
154 Reinhart, William  Aug 1885New York State I1062
155 Salos, Elizabeth  Abt 1918New York State I323
156 Schwenk, Christian Burton  14 May 1951New York State I754
157 Sigeti, Anna V  Abt 1913New York State I339
158 Sigeti, Anthony J  25 Jun 1921New York State I326
159 Sigeti, Bertha F  Abt 1922New York State I328
160 Sigeti, Frank W  Abt 1927New York State I330
161 Sigeti, Helen E  Abt 1917New York State I333
162 Sigeti, Julia C  Abt 1914New York State I334
163 Sigeti, Marie I.  29 Nov 1911New York State I294
164 Sigeti, Steve  Abt 1919New York State I332
165 Stephan, Amalia  Abt 1862New York State I991
166 Stephan, Levina  Abt 1869New York State I989
167 Stephan, Rosa  Abt 1864New York State I990
168 Strohe, Florence  11 Dec 1889New York State I918
169 Tobin, Charles  Abt 1878New York State I899
170 Tobin, Joseph  14 Sep 1890New York State I894
171 Tobin, Mary  Abt 1876New York State I900
172 Tobin, Thomas Albert  15 Nov 1893New York State I893
173 Valiquette, Amelia  Abt 1852New York State I1010
174 Valiquette, George C.  Abt 1864New York State I1034
175 Valiquette, John  Abt 1862New York State I1037
176 Valiquette, Peter  Feb 1855New York State I738
177 Ververs, Mary V  Abt 1903New York State I1128
178 Voght, Louis  Abt 1874New York State I820
179 Vogt, Arthur W.  Abt 1886New York State I813
180 Vogt, Cary  Abt 1872New York State I818
181 Vogt, Cora  Abt 1884New York State I816
182 Vogt, Eugene  Abt 1866New York State I821
183 Vogt, Laura  Abt Feb 1870New York State I814
184 Vogt, Leon  Abt 1874New York State I817
185 Willman, Clara  Abt 1874New York State I823
186 Willman, Ida  Abt 1878New York State I824
187 Willman, Joseph  Abt 1869New York State I829
188 Willman, Julie  Abt Apr 1870New York State I827
189 Willman, Leo  Abt 1876New York State I828
190 Willman, Mary Eleanor  Abt 1867New York State I826

Death

Matches 1 to 8 of 8

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID 
1 Catharine  Bef 1900New York State I777
2 Bisantz, Anthony Edward Jr.  16 Apr 1875New York State I739
3 Flanigan, John  8 Nov 1963New York State I327
4 Flanigan, William J.  28 Jun 1961New York State I911
5 Kingsland, Gordon  Abt Jul 1979New York State I350
6 Licino, Felicia “Chicky”  20 Dec 1999New York State I261
7 McNamara, Delia  11 Dec 1964New York State I788
8 Santercole, Louis V.  27 Jan 2015New York State I1231

Arrival

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Arrival    Person ID 
1 Licino, Michael "Mike"  7 Mar 1919New York State I260

Birth

Matches 1 to 9 of 9

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Berst, Dorothy  Abt 1923New York State I962
2 Bisantz, Dominic "Daniel"  12 May 1849New York State I765
3 Bisantz, Mary  Abt 1846New York State I880
4 Caldiero, Carmine  Abt 1916New York State I343
5 Clare, Julia  Abt 1867New York State I1047
6 Clare, Mary Ann  4 Aug 1872New York State I1045
7 Clark, Michael John  Abt 1906New York State I1078
8 Flanigan, Helen Louse  Abt 1926New York State I909
9 Okoski, Ida  Mar 1873New York State I1035

Death

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID 
1 Kingsland, Gordon  17 Jul 1979New York State I350

Military Service Record

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Military Service Record    Person ID 
1 McCormick, Philip  10 Oct 1864New York State I794

Residence

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID 
1 Sigeti, Anthony J  New York State I326