Pitard.net - Buffalo Family

New York State



 


Country : Latitude: 42.616645309, Longitude: -75.785757956


Birth

Matches 1 to 193 of 193

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Willman, Mary Eleanor  Abt 1867New York State I826
2 Willman, Leo  Abt 1876New York State I828
3 Willman, Julie  Abt Apr 1870New York State I827
4 Willman, Joseph  Abt 1869New York State I829
5 Willman, Ida  Abt 1878New York State I824
6 Willman, Clara  Abt 1874New York State I823
7 Vogt, Leon  Abt 1874New York State I817
8 Vogt, Laura  Abt Feb 1870New York State I814
9 Vogt, Eugene  Abt 1866New York State I821
10 Vogt, Cora  Abt 1884New York State I816
11 Vogt, Cary  Abt 1872New York State I818
12 Vogt, Arthur W.  Abt 1886New York State I813
13 Voght, Louis  Abt 1874New York State I820
14 Ververs, Mary V  Abt 1903New York State I1128
15 Valiquette, Peter  Feb 1855New York State I738
16 Valiquette, John  Abt 1862New York State I1037
17 Valiquette, George C.  Abt 1864New York State I1034
18 Valiquette, Amelia  Abt 1852New York State I1010
19 Tobin, Thomas Albert  15 Nov 1893New York State I893
20 Tobin, Mary  Abt 1876New York State I900
21 Tobin, Joseph  14 Sep 1890New York State I894
22 Tobin, Charles  Abt 1878New York State I899
23 Strohe, Florence  11 Dec 1889New York State I918
24 Stephan, Rosa  Abt 1864New York State I990
25 Stephan, Levina  Abt 1869New York State I989
26 Stephan, Amalia  Abt 1862New York State I991
27 Smith, John J.  Oct 1852New York State I475
28 Sigeti, Steve  Abt 1919New York State I332
29 Sigeti, Marie I.  29 Nov 1911New York State I294
30 Sigeti, Julia C  Abt 1914New York State I334
31 Sigeti, Helen E  Abt 1917New York State I333
32 Sigeti, Frank W  Abt 1927New York State I330
33 Sigeti, Bertha F  Abt 1922New York State I328
34 Sigeti, Anthony J  25 Jun 1921New York State I326
35 Sigeti, Anna V  Abt 1913New York State I339
36 Schwenk, Christian Burton  14 May 1951New York State I754
37 Salos, Elizabeth  Abt 1918New York State I323
38 Reinhart, William  Aug 1885New York State I1062
39 Reinhart, Phillipana  May 1882New York State I1065
40 Reinhart, Martha A  May 1884New York State I1064
41 Reinhart, John P  Nov 1889New York State I1061
42 Reinhart, Jennie  Jan 1881New York State I1059
43 Reinhart, James  May 1884New York State I1063
44 Reinhardt, Philipine  Abt 1856New York State I1190
45 Reinhardt, Magdalene  Abt 1854New York State I1191
46 Reinhardt, Joseph  Dec 1851New York State I1055
47 Reinhardt, Frank  Abt 1860New York State I1192
48 Reinhardt, Emma  Apr 1878New York State I1060
49 Reinhardt, Dominia  Abt 1858New York State I1193
50 Ramé, Valentine  Abt 1841New York State I855
51 Ramé, Marian  Mar 1847New York State I853
52 Ramé, Margaret Victoria  Jun 1848New York State I852
53 Ramé, Lewis  Abt 1837New York State I854
54 Ramé, Anthony  Abt 1847New York State I857
55 Paul, Loretta A.  Abt 1909New York State I1040
56 Paul, Florence M.  Abt 1908New York State I1039
57 Paul, Anthony M.  Abt 1879New York State I1038
58 Paolucci, Serafino  17 Feb 1915New York State I369
59 Paolucci, Guido  Abt 1921New York State I362
60 Paolucci, Dominick  Abt 1927New York State I363
61 Paolucci, Clara  21 Jan 1923New York State I364
62 Paolucci, Angeline Frances  Abt 1919New York State I361
63 Palermo, Thomas  Abt 1915New York State I263
64 Palermo, Theresa  Abt 1914New York State I264
65 Palermo, Felicia A. "Fanny"  Jan 1912New York State I214
66 Palermo, Fannie  Abt Dec 1909New York State I262
67 Palermo, Carmine "Charlie"  22 Aug 1913New York State I218
68 Okoski, Ida  Abt 1873New York State I1035
69 Nichols, Robert  Abt Mar 1880New York State I1242
70 Nichols, Nellie  Abt 1875New York State I1237
71 Nichols, Mary Bell  Abt 1872New York State I1238
72 Nichols, Lottie  Abt 1878New York State I1243
73 Nichols, Eva  Abt 1876New York State I1244
74 Nichols, Charles  Abt 1861New York State I1241
75 Nichols, Catherine  Abt 1863New York State I1239
76 Nicholas, Elizabeth  Abt 1859New York State I1240
77 Moser, Fredericka  Abt 1858New York State I958
78 Moser, Frederick  Abt 1855New York State I959
79 Moser, Anna E.  Oct 1855New York State I721
80 McMullen, Matilda "Tillie"  Jun 1885New York State I1072
81 McMullen, James "Jim" W.  Apr 1860New York State I1068
82 McMullen, Frederic J. “Fred”  Jul 1888New York State I1070
83 McMullen, Frances "Fannie"  Nov 1886New York State I1073
84 McMullen, Clark Augustine  20 Jan 1890New York State I1069
85 McMullen, Anne Marie  Nov 1894New York State I1071
86 McCormick, Mary  Abt 1858New York State I741
87 Martin, Carl  Abt 1905New York State I1228
88 Logalbo, Vincent C. "Jimmy"  30 Sep 1912New York State I215
89 Logalbo, Joseph  Abt 1912New York State I325
90 Logalbo, Antonina "Nina"  Abt 1915New York State I324
91 Licino, Felicia “Chicky”  13 Mar 1913New York State I261
92 Kingsland, Walter  Abt 1902New York State I388
93 Kingsland, Gordon  9 Nov 1915New York State I350
94 Jordan, William Lee  Abt 1915New York State I971
95 Jordan, William  Jan 1887New York State I947
96 Jordan, Rita  Abt 1915New York State I723
97 Jordan, Matthew W.  9 Aug 1882New York State I714
98 Jordan, Mary  Abt 1924New York State I728
99 Jordan, Mary  Aug 1890New York State I946
100 Jordan, M. Katherine  1907New York State I724
101 Jordan, Joseph S.  Jul 1892New York State I948
102 Jordan, Joseph E  Abt 1914New York State I972
103 Jordan, John  Abt 1849New York State I936
104 Jordan, Henry  Sep 1882New York State I949
105 Jordan, Anna  May 1883New York State I945
106 Gallagher, Irene M  Abt 1892New York State I973
107 Fries, Walter  Aug 1881New York State I999
108 Fries, Louis  May 1885New York State I860
109 Fries, Joseph  Apr 1887New York State I997
110 Fries, Charles  Abt 1877New York State I998
111 Fries, Charles  Abt 1853New York State I859
112 Fries, Blanche  Feb 1892New York State I996
113 Forster, Lucille Catherine  15 Apr 1921New York State I1230
114 Flanigan, James T.  Mar 1890New York State I1234
115 Flanigan, Helen  Apr 1894New York State I1232
116 Flanigan, Charlotte  Dec 1892New York State I1233
117 Flanigan, Charlotte  Oct 1857New York State I1226
118 Farnes, Clara  Jul 1873New York State I365
119 Farnes, Anthony  Abt 1850New York State I1054
120 Denzinger, Olivia  Abt 1868New York State I832
121 Denzinger, Julius  Abt 1870New York State I831
122 Denzinger, Charles  Abt 1866New York State I833
123 Darsheimer, Ethel  Abt 1894New York State I907
124 Cuoco, Theresa "Cookie"  Abt 1919New York State I279
125 Cuoco, Concetta  Abt 1926New York State I277
126 Cuoco, Angelo  6 Dec 1932New York State I280
127 Cuoco, Albert  28 Oct 1921New York State I278
128 Corigliano, Samuel  Abt 1923New York State I357
129 Corigliano, Rose  Abt 1895New York State I347
130 Corigliano, Philip  Abt 1914New York State I360
131 Corigliano, Lucy  Abt 1915New York State I359
132 Corigliano, Grace  Abt 1920New York State I358
133 Corigliano, Angeline  Abt 1912New York State I344
134 Colpoys, Matthew  25 Sep 1936New York State I785
135 Colpoys, Mae  21 Feb 1900New York State I1214
136 Colpoys, Lillian  19 Nov 1903New York State I1215
137 Colpoys, Henry F.  26 Sep 1905New York State I1212
138 Colpoys, Francis T.  Abt 1910New York State I1210
139 Colpoys, Edward "Eddie" J.  22 Jul 1912New York State I784
140 Colpoys, Cecelia M.  Abt 1909New York State I1217
141 Colpoys, Arthur M.  13 Jan 1902New York State I1213
142 Colpoys, Agnes F.  14 Jun 1907New York State I1211
143 Collins, Henry  Jul 1868New York State I544
144 Collins, Anthony  May 1872New York State I545
145 Clark, William J. "Bill"  Abt 1902New York State I1080
146 Clark, Thomas  Abt 1856New York State I3
147 Clark, Peter  Abt 1864New York State I979
148 Clark, Michael  Abt 1873New York State I984
149 Clark, Martha  Abt 1861New York State I986
150 Clark, Maria  Abt 1860New York State I980
151 Clark, James  Aug 1862New York State I978
152 Clark, Fannie  Abt 1858New York State I976
153 Clark, Elizabeth "Libbie"  Abt 1868New York State I985
154 Clark, Bridget  Abt 1858New York State I981
155 Clark, Anna  Mar 1867New York State I983
156 Clare, Mary Sophia  1860New York State I1043
157 Caldiero, Mary  Abt 1913New York State I232
158 Buckley, Adeline  Abt 1878New York State I1079
159 Bouquard, Peter  Sep 1882New York State I1019
160 Bouquard, Kate  Dec 1888New York State I1015
161 Bouquard, Josephine  Jun 1896New York State I1014
162 Bouquard, Joseph  Abt 1854New York State I1013
163 Bouquard, Harry  Apr 1890New York State I1016
164 Bouquard, Frank  Jan 1881New York State I1020
165 Bouquard, Andrea  Dec 1885New York State I1018
166 Bisky, Marcella Patricia  Abt 1902New York State I1086
167 Bisantz, Mary Magdalena  3 Feb 1838New York State I772
168 Bisantz, Mary Elizabeth  6 Dec 1842New York State I768
169 Bisantz, Mary  Abt 1841New York State I880
170 Bisantz, John  Abt 1839New York State I879
171 Bisantz, Frank J.  Abt 1849New York State I882
172 Bisantz, Dominic "Daniel"  Abt 1849New York State I765
173 Bisantz, Charles  Abt 1845New York State I884
174 Bisantz, Catherine M.  Mar 1840New York State I767
175 Bisantz, Augusta  Abt 1847New York State I771
176 Biesanz, Michael  Abt 1854New York State I883
177 Berst, Peter  Oct 1855New York State I1195
178 Berst, Mary  Jan 1890New York State I1197
179 Berst, Mary  Mar 1858New York State I1194
180 Berst, Lillian  Apr 1882New York State I1199
181 Berst, Gertrude  Jul 1891New York State I1196
182 Berst, Edward  Jul 1885New York State I1198
183 Battista, Thomas "Honey"  18 Feb 1906New York State I252
184 Battista, Rosina "Rose"  23 Mar 1892New York State I255
185 Battista, Nancy  29 Apr 1902New York State I245
186 Battista, Mildred "Millie"  Abt 1915New York State I254
187 Battista, Margaret "Maggie"  3 Dec 1899New York State I248
188 Battista, Luigi "Louis"  17 Sep 1897New York State I246
189 Battista, Ellen  Abt 1903New York State I244
190 Barry, Theresa C.  Abt 1855New York State I503
191 Mary  Aug 1863New York State I1092
192 Elizabeth  Abt 1909New York State I1222
193 Elizabeth  Abt 1906New York State I284

Death

Matches 1 to 8 of 8

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID 
1 Santercole, Louis V.  27 Jan 2015New York State I1231
2 McNamara, Delia  11 Dec 1964New York State I788
3 Licino, Felicia “Chicky”  20 Dec 1999New York State I261
4 Kingsland, Gordon  Abt Jul 1979New York State I350
5 Flanigan, William J.  28 Jun 1961New York State I911
6 Flanigan, John  8 Nov 1963New York State I327
7 Bisantz, Anthony Edward Jr.  16 Apr 1875New York State I739
8 Catharine  Bef 1900New York State I777

Arrival

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Arrival    Person ID 
1 Licino, Michael "Mike"  7 Mar 1919New York State I260

Birth

Matches 1 to 9 of 9

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Okoski, Ida  Mar 1873New York State I1035
2 Flanigan, Helen Louse  Abt 1926New York State I909
3 Clark, Michael John  Abt 1906New York State I1078
4 Clare, Mary Ann  4 Aug 1872New York State I1045
5 Clare, Julia  Abt 1867New York State I1047
6 Caldiero, Carmine  Abt 1916New York State I343
7 Bisantz, Mary  Abt 1846New York State I880
8 Bisantz, Dominic "Daniel"  12 May 1849New York State I765
9 Berst, Dorothy  Abt 1923New York State I962

Death

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID 
1 Kingsland, Gordon  17 Jul 1979New York State I350

Military Service Record

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Military Service Record    Person ID 
1 McCormick, Philip  10 Oct 1864New York State I794

Residence

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID 
1 Sigeti, Anthony J  New York State I326